S-8 1 s-8ltipadditionalshares.htm S-8 Document
于2024年10月29日向证券交易委员会提交
登记号333-

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
____________________________
S-8表格
注册声明
根据.
代表股份的存托凭证
image_1a.jpg
Renasant公司
(根据其章程规定的注册人准确名称)

    
        密西西比州                        64-0676974
(州或其他(I.R.S.雇主
公司注册地 识别号码)
或组织)

209号特洛伊街
密西西比州图佩洛市 38804-4827
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
image_1a.jpg
Renasant公司
2020年长期激励报酬计划
Ileana McAlary
image_1a.jpg
C. MITCHELL WAYCASTER抄送:
首席执行官MARk W. JEANFREAU
renasant公司总法律顾问
209号特洛伊街renasant公司
密西西比州图佩洛市 38804-4827209号特洛伊街
(662) 680-1001密西西比州图佩洛市 38804-4827
(名称和地址,包括邮政编码,以及电话号码,
Henry Nisser, Esq.
(662) 680-1445
请勾选标记以说明注册人是大型快速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请查看《交易所法》第120亿.2条中“大型快速申报人”、“加速申报人”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速报告人加速文件申报人
非加速文件提交人更小的报告公司
新兴成长公司
如果是新兴成长型公司,请勾选是否已选择不使用根据交易所法案第13(a)条款提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期来遵守。







说明:

该Form S-8注册声明表格(“注册声明表格”)是为注册额外的915,000股普通股,每股面值为5.00美元(“股票”),在Renasant Corporation(“renasant”)名下。苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。)目的在于注册额外的915,000股普通股,面值为5.00美元每股(“股票”)。普通股”)旗下的Renasant Corporation(“renasant”)公司”或“公司申请人根据renasant公司2020年长期激励报酬计划(以下简称“该计划”)授予的奖励,可以发行401(k)计划的雇主贡献,此项增加已经获得公司股东于2024年4月23日公司股东年度会议批准。该公司此前已向证券交易所提交了委员会:,于2020年5月18日,在表格S-8(SEC文件号333-238480)上注册了计划下的180万股普通股。先前的登记声明”,于2020年5月18日,在表格S-8(SEC文件号333-238480)上注册了计划下的180万股普通股。
本注册声明与先前注册声明相关联的同类证券有关,并根据S-8表格的E通用指示提交,用于注册额外证券。根据S-8表格的E通用指示,先前注册声明的内容通过引用并成为本注册声明的一部分,除非此处已被替换。
第一部分
第10(a)区间申报所需的信息
根据表格S-8第I部分要求的信息,与本登记声明相关的拟议书已根据表格S-8第I部分的注释被省略。计划下的每位权益奖项持有人将收到拟议书副本或包含表格S-8第I部分指定信息的文件,根据1933年证券法的第428(b)(1)规定。根据委员会规定,计划的拟议书不会随本登记声明一并提交或纳入。

第II部分
注册声明所需的信息

第三项。通过文档参考纳入。
公司根据1934年修正《证券交易法》提交给委员会的文件如下使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;该等文件依据美国1934年修订的《证券法》和《证券交易所法》(以下简称“”)已由申请人向美国证券交易委员会备案,并适用于本文件:
a) 公司2023年度财年截至12月31日的10-k表格年度报告,于2024年2月23日提交给委员会;
b) 公司于2024年3月31日结束的财季提交给委员会的10-Q表格,于2024年5月8日提交;公司于2024年6月30日结束的财季提交给委员会的10-Q表格,于2024年8月7日提交;
公司当前的8-k表格申报已于2024年4月23日提交给委员会(仅就条款5.02下的信息而言),2024年4月25日提交给委员会(仅就条款3.03、5.02、5.07和9.01下的信息而言),2024年7月2日,2024年7月29日提交给委员会(仅就条款1.01、8.01和9.01下的信息而言),2024年7月30日提交给委员会(仅就条款1.01和9.01下的信息而言)(除了被视为提供而非申报的文件部分),以及2024年10月24日;及




d) 公司于2024年8月28日向委员会提交的8-A/A登记声明中所包含的普通股描述,其中提及了公司于2024年8月7日向委员会提交的10-Q季度报告中的附件4.1,包括为更新此描述而提交的任何后续修订或报告。
就8-k表格上的任何报告或其中任何附注中包含的信息,如果是提供给委员会而不是提交给委员会,这些信息或附注明确不会被引入此处。
根据交易所法案第13(a)、13(c)、14和15(d)条的规定,自本注册声明日期之后的交易所法案的所有文件,直至提交表明所有本处所提供证券已售出,或注销所有尚未售出证券的后续有效修正登记,应视为被纳入本注册声明,并自提交这些文件之日起成为本注册声明的一部分,前提是这些文件中包含的任何文件或信息被视为“提供”给或未被“提交”给证监会,并符合证监会规定,包括但不限于公司的薪酬委员会报告和绩效图表以及根据8-k表中2.02和7.01项提供的信息,以及相关附件,在本注册声明中不被视为被纳入其中。本注册声明中包含的或被视为被纳入其中的文件中的任何声明,在本注册声明的目的上应被视为被修改或取代,以便在此处包含的声明或任何其他随后提交的文件中,这些文件也被视为被纳入本文件修改或取代了这样的声明。被修改或取代的任何此类声明不应被视为构成本注册声明的一部分,除非经修改或取代。

附件。

Exhibit No.    Description of Exhibit



107.1*    Filing Fee Table

* Filed herewith.



SIGNATURES

    Pursuant to the requirements of the Securities Act of 1933, as amended, the Registrant certifies that it has reasonable grounds to believe that it meets all of the requirements for filing on Form S-8 and has duly caused this Registration Statement to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized, in the City of Tupelo, State of Mississippi, on this 29th day of October 2024.

                            RENASANT CORPORATION
        
                
    By: /s/ C. Mitchell Waycaster            
C. Mitchell Waycaster
Chief Executive Officer                    




POWER OF ATTORNEY

    KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, that we, the undersigned directors and officers of Renasant Corporation, constitute and appoint C. Mitchell Waycaster, Kevin D. Chapman and James C. Mabry IV and each or any of them (with full power to each act alone), our true and lawful agents and attorneys-in-fact, for us and on our behalf and in our name, place and stead, in any and all capacities, to sign, execute, acknowledge, deliver, and file with the Securities and Exchange Commission (or any other governmental or regulatory authority) any and all amendments (including post-effective amendments) to this Registration Statement on Form S-8, and to file the same with all exhibits thereto, and all other documents in connection therewith and all instruments necessary, appropriate or advisable to enable Renasant Corporation to comply with the Securities Act of 1933, as amended, and other federal and state securities laws, in connection with the Renasant Corporation 2020 Long-Term Incentive Compensation Plan, as amended, and to do and perform each and every act and thing requisite and necessary to be done, as fully and for all intents and purposes as we might or could do in person, hereby ratifying and confirming all that said attorneys-in-fact and agents or any of them or their substitutes may lawfully do or cause to be done by virtue hereof.
Pursuant to the requirements of the Securities Act of 1933, as amended, this Registration Statement has been signed by the following persons in the capacities and on the dates indicated.


Date: October 29, 2024by:
  /s/ C. Mitchell Waycaster            
C. Mitchell Waycaster
Director, Chief Executive Officer and Executive Vice Chairman (Principal Executive Officer)
Date: October 29, 2024by:
  /s/ James. C. Mabry IV                
James C. Mabry IV
Executive Vice President and Chief Financial Officer
(Principal Financial Officer)


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Kelly W. Hutcheson                
Kelly W. Hutcheson
Chief Accounting Officer
(Principal Accounting Officer)

Date: October 29, 2024by:
  /s/ E. Robinson McGraw            
E. Robinson McGraw
Executive Chairman, Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Gary D. Butler                
Gary D. Butler, Director





Date: October 29, 2024by:
  /s/ Donald Clark, Jr.                
Donald Clark, Jr., Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ John M. Creekmore            
John M. Creekmore, Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Albert J. Dale, III                
Albert J. Dale, III, Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Jill V. Deer                
Jill V. Deer, Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Connie L. Engel                
Connie L. Engel, Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Rose J. Flenorl                
Rose J. Flenorl, Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ John T. Foy                
John T. Foy, Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Richard L. Heyer, Jr.            
Richard L. Heyer, Jr., Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Neal A. Holland, Jr.            
Neal A. Holland, Jr., Director


Date: October 29, 2024by:
  /s/ Sean M. Suggs                
Sean M. Suggs, Director